European Patent Office
1996

10 - Oktober

Übersicht

Inhaltsverzeichnis
1-2 - Januar - Februar
3 - März
4 - April
5 - Mai
6 - Juni
7 - Juli
8 - August
9 - September
10 - Oktober
11 - November
12 - Dezember
Beilagen / Sonderausgaben
Beilage to OJ 3/1996
Sonderausgaben
Beilage to OJ 12/1996
Beilage 2 to OJ 12/1996

    Seiten 606-611

    Referenz: ABl. EPA 1996, 606

    Online-Veröffentlichungsdatum: 31.10.1996

    VERTRETUNG

    Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter*

    CH — Schweiz / Switzerland / Suisse

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Nielsen, Hans Joachim (DE)

    Patentanwälte

    Schaad, Balass, Menzl & Partner

    Dufourstrasse 101

    Postfach

    CH-8034 Zürich

    DE — Deutschland / Germany / Allemagne

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Neubauer, Hans-Joachim (DE)

    Im Lindegewann 15

    D-65191 Wiesbaden

     

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Andrae, Steffen (DE)

    Andrae Flach Haug Kneissl

    Bauer Schneider

    Balanstraße 55

    D-81541 München

    Bauer, Friedrich (DE)

    Andrae Flach Haug Kneissl

    Bauer Schneider

    Prinzregentenstraße 24

    D-83022 Rosenheim

    Flach, Dieter Rolf Paul (DE)

    Andrae Flach Haug Kneissl

    Bauer Schneider

    Prinzregentenstraße 24

    D-83022 Rosenheim

    Haug, Dietmar (DE)

    Andrae Flach Haug Kneissl

    Bauer Schneider

    Balanstraße 55

    D-81541 München

    Hirsch, Hans-Ludwig (DE)

    Kraft Jacobs Suchard R&D, Inc.

    Postfach 83 05 50

    D-81705 München

    Hofstetter, Alfons J. (DE)

    Strasse & Hofstetter

    Balanstraße 55

    D-81541 München

     

    Kneissl, Richard (DE)

    Andrae Flach Haug Kneissl

    Bauer Schneider

    Balanstraße 55

    D-81541 München

    Pauling, Hans-Jürgen (DE)

    Patze - Neumeister - Jägersberg

    August-Bebel-Platz 8

    D-06108 Halle

    Rausch, Gabriele (DE)

    Heidehofstraße 6

    D-70184 Stuttgart

    Richardt, Markus Albert (DE)

    Patentanwalt

    Dipl.-Ing. Markus A. Richardt

    Wiesenstraße 35 a

    D-65344 Eltville

    Strasse, Joachim (DE)

    Strasse & Hofstetter

    Balanstraße 55

    D-81541 München

    Wellner, Hans (DE)

    Sonnenblick 1

    D-08340 Beierfeld

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Janotte, Michael (DE) - R. 102(1)

    Homburger Landstraße 10

    D-61440 Oberursel

    Lucas, Ina (DE) - R. 102(1)

    Viertelsweg 13

    D-04157 Leipzig

     

    DK — Dänemark / Denmark / Danemark

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Kjerrumgaard, Bent (DK)

    Mariendalsvej 37 B, 3.th

    DK-2000 Frederiksberg

    ES — Spanien / Spain / Espagne

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Benitez Benitez, Rafael (ES) - R. 102(2)c), R. 102(1)

    Avda. Luis de Morales, 32

    Edificio Forum

    Oficina 216

    E-41005 Sevilla

    Moreno Gomez, Enrique (ES) - R. 102(2)c), R. 102(1)

    Calle Recoletos, 12-3. dcha.

    E-28001 Madrid

    Palazon Aznar, Rogelio Ramon (ES) - R. 102(2)c), R. 102(1)

    Calle Valencia 305, 2.

    E-08009 Barcelona

    Plaza y Saenz de Cenzano, Francisco (ES) - R. 102(2)c), R. 102(1)

    Gran Via, 22 dupl

    E-28013 Madrid

    Valdes Moreiras, Eusebio (ES) - R. 102(2)c), R. 102(1)

    Juan Ramon Jimenez 2 5-H

    E-28036 Madrid

     

    FI — Finnland / Finland / Finlande

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Hakkila, Maini Annika (FI)

    Forssén & Salomaa Oy

    Yrjönkatu 30

    FIN-00100 Helsinki

    Hakola, Unto Tapani (FI)

    Tampereen Patenttitoimisto Oy

    Hermiankatu 6

    FIN-33720 Tampere

    Kahilainen, Hannu Juhani (FI)

    Tampereen Patenttitoimisto Oy

    Hermiankatu 6

    FIN-33720 Tampere

    Pursiainen, Timo Pekka (FI)

    Tampereen Patenttitoimisto Oy

    Hermiankatu 6

    FIN-33720 Tampere

    FR — Frankreich / France

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Remy, Jean Louis (FR)

    ANVAR AQUITAINE

    Les Bureaux du Lac II

    39, rue Robert Caumont

    F-33049 Bordeaux Cedex

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Boireau, Jacques (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

     

    Bourely, Paul (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Buffiere, Michelle (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    El Manouni, Josiane (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Feray, Valérie (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Fournier, Michel Robert Marie (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Fournier, Michel (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

     

    Gosse, Michel (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Laroche, Danièle (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Marek, Pierre (FR)

    Cabinet Marek

    28, rue de la Loge

    F-13235 Marseille Cedex 02

    Pothet, Jean Rémy Emile Ludovic (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Prugneau, Philippe (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Renaud-Goud, Thierry (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Schaub, Bernard (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

     

    Scheer, Luc (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Sciaux, Edmond (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Smith, Bradford Lee (US)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    Vigand, Privat (FR)

    Alcatel Alsthom

    Département Propriété Industrielle

    30, avenue Kléber

    F-75116 Paris

    GB — Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Connell, Anthony Christopher (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horisons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Dalton, Marcus Jonathan William (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

     

    Denholm, Anna Marie (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Fawcett, Richard Fennelly (GB)

    63 Pope's Avenue

    Strawberry Hill

    GB-Twickenham, Middlesex TW2 5TD

    Florence, Julia Anne (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horisons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Giddings, Peter John (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Hale, Stephen Geoffrey (GB)

    J.Y. & G.W. Johnson

    Kingsbourne House

    229-231 High Holborn

    GB-London WC1V 7DP

    Horner, David Richard (GB)

    D. Young & Co.

    21 London Road

    GB-Southampton, Hants. SO15 2AD

     

    Kirk, Martin John (GB)

    The Boots Company plc

    Group Patents Department

    D31

    1 Thane Road West

    GB-Nottingham NG2 3AA

    Lawton, Peter Philip (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horisons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Manaton, Ross Timothy (GB)

    JY & GW Johnson

    Kingsbourne House

    229-231 High Holborn

    GB-London WC1V 7DP

    Newby, Martin John (GB)

    J Y & G W Johnson

    Kingsbourne House

    229-231 High Holborn

    GB-London WC1V 7DP

    Newby, John Ross (GB)

    J.Y. & G.W. Johnson

    Kingsbourne House

    229-231 High Holborn

    GB-London WC1V 7DP

    Phillips, Margaret Dawn (GB)

    Rank Xerox Ltd.

    Patent Separtment

    Parkway

    GB-Marlow, Bucks. SL7 1YL

     

    Reeves, Julie Frances (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Roberts, David (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Russell, Brian John (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Rutter, Keith (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great west Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Shackleton, Nicola (GB)

    Page White & Farrer

    54 Doughty Street

    GB-London WC1N 2LS

    Smith, Elizabeth Jane (GB)

    The Boots Company plc

    Group Patents Department

    D31

    1 Thane Road West

    GB-Nottingham NG2 3AA

     

    Summersell, Richard John (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Thompson, Clive Beresford (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Tocher, Pauline (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Treacher, Alan Leslie (GB)

    Avdel Textron Limited

    Intellectual Property Department

    Mundells

    GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1EZ

    Tyrrell, Arthur William Russell (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Valentine, Jill Barbara (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

     

    Walker, Ralph Francis (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 EPD

    Waters, David Martin (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    West, Vivien (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    White, Susan Mary (GB)

    SmithKline Beecham plc

    Corporate Intellectual Property

    New Horizons Court - 2/NHC/1

    Great West Road

    GB-Brentford, Middlesex TW8 9EP

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Brown, Peter A. (GB) - R. 102(2)c), R. 102(1)

    McCarthy & McCarthy

    141 Moorgate

    5th Floor

    GB-London EC2M 6TX

    Rowe, Eric Nielsen (GB) - R. 102(1)

    20 Willow Gardens

    GB-Hounslow, Middlesex TW3 4JS

     

    IT — Italien / Italy / Italie

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Galletti di San Cataldo, Vettor (IT) - R. 102(2)c), R. 102(1)

    Via XX settembre 36

    I-16121 Genova

    Saviotti, Guidobaldo (IT) - R. 102(1)

    P.le S. di Santarosa, 4

    I-20156 Milano

    NL — Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Schoenmaker, Maarten (NL)

    Octrooibureau LIOC B.V.

    P.O. Box 85096

    NL-3508 AB Utrecht

    SE — Schweden / Sweden / Suède

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Engholm, Carl (SE)

    Pharmacia & Upjohn AB

    Patent Department

    S-751 82 Uppsala

    Hopfgarten, Nils (SE)

    L.A. Groth & Co. KB

    P.O. Box 6107

    S-102 32 Stockholm

    Widén, Björn (SE)

    Pharmacia & Upjohn AB

    Patent Department

    S-751 82 Uppsala

     

     

    _______

    * Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).

    Anschrift:

    EPI-Generalsekretariat

    Erhardtstraße 27

    D-80331 München

    Tel. (+49-89)2017080

    Tx. 5/216834

    FAX (+49-89)2021548

    Unterstützung

    • Aktualisierungen der Website
    • Verfügbarkeit der Online-Dienste
    • FAQ
    • Veröffentlichungen
    • Verfahrensbezogene Mitteilungen
    • Kontakt
    • Aboverwaltung
    • Offizielle Feiertage
    • Glossar

    Jobs & Karriere

    Pressezentrum

    Single Access Portal

    Beschaffung

    Beschwerdekammern

    Facebook
    European Patent Office | EPO Jobs
    Instagram
    EuropeanPatentOffice
    Linkedin
    European Patent Office | EPO Jobs | EPO Procurement
    X (formerly Twitter)
    EPOorg | EPOjobs
    Youtube
    TheEPO
    ImpressumNutzungsbedingungenDatenschutzBarrierefreiheit