European Patent Office
2000

1 - janvier

Vue d'ensemble

Table des matières
1 - janvier
2 - février
3 - mars
4 - avril
5 - mai
6 - juin
7 - juillet
8-9 - août - septembre
10 - octobre
11 - novembre
12 - décembre
Suppléments / Éditions spéciales
Supplément to OJ 4/2000
Supplément to OJ 11/2000
Éditions spéciales

    Pages 32-37

    Référence : JO OEB 2000, 32

    Date de publication en ligne: 28.1.2000

    REPRÉSENTATION

    Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets1

    AT — Österreich / Austria / Autriche

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Szász, Tibor Josef (AT) - R. 102(1)

    Patentanwalt

    Dipl.-Ing. Tibor Josef Szász

    Elisabethallee 81/1/4

    A-1130 Wien

    BE — Belgien / Belgium / Belgique

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Verbrugghe, Anne Marie L. (BE)

    Agfa-Gevaert N.V.

    Corporate IP Department

    Septestraat 27

    B-2640 Mortsel

    CH — Schweiz / Switzerland / Suisse

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Felder, Peter (CH)

    Schmauder & Partner AG

    Zwängiweg 7

    CH-8038 Zürich

    Hassenbürger, Anneliese (DE)

    Novartis AG

    Geistiges Eigentum Konzern

    Patent- und Markenabteilung CH

    Postfach

    CH-4002 Basel

    Surmely, Gérard (CH)

    I C B

    Ingénieurs Conseils en Brevets SA

    Rue des Sors 7

    CH-2074 Marin

    von Sprecher, Georg (CH)

    Novartis AG

    Patent- und Markenabteilung CH

    Postfach

    CH-4002 Basel

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Jansen, Götz (DE)

    Imfeldstraße 47

    CH-8037 Zürich

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Siebert, Rolf (CH) - R. 102(1)

    Patentanwaltsbureau R.A. Maspoli

    Postfach 191

    Witikonerstrasse 279

    Witikon - Zentrum

    CH-8053 Zürich

    DE — Deutschland / Germany / Allemagne

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    de Groot, Ute (DE)

    Schott Glas

    Patente III

    Hattenbergstraße 10

    D-55122 Mainz

    Dörr, Klaus (DE)

    Aventis Research &

    Technologies GmbH & Co KG

    Industriepark

    Hoechst - Gebäude K 801

    D-65926 Frankfurt am Main

    Draudt, Jutta (DE)

    Zeppelinstraße 12

    D-85521 Riemerling

    Garrels, Sabine (DE)

    Maßmannstraße 104

    D-18057 Rostock

    Herbst, Matthias Heinz (DE)

    Siemens AG

    ZT PA 4

    Paul-Gossen-Straße 100

    D-91052 Erlangen

    Herrmann, Franz (DE)

    Epping Herrmann & Peter

    Patentanwälte

    Ridlerstraße 55

    D-80339 München

    Huhn, Michael (DE)

    Bardehle - Pagenberg - Dost

    Altenburg - Geissler - Isenbruck

    Patent- und Rechtsanwälte

    Theodor-Heuss-Anlage 12

    D-68165 Mannheim

    Kremer, Viola (DE)

    Hoechst Trespaphan GmbH

    John-F.-Kennedy-Straße 4

    D-66539 Wiesbaden

    Mahrt, Kurt (DE)

    DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

    FTP/B-N

    Frankenstraße 140

    D-90461 Nürnberg

    Pohl, Michael Friedrich (DE)

    Reitstötter, Kinzebach &

    Partner (GbR)

    Postfach 21 11 60

    D-67011 Ludwigshafen

    Rietzler, Alwin (DE)

    Epping Hermann & Peter

    Patentanwälte

    Ridlerstraße 55

    D-80339 München

    Schäfer, Horst (DE)

    Siemens AG

    ZT PA

    Postfach 22 16 34

    D-80506 München

    Seißler, Michael (DE)

    Siemens AG

    ZT PA 6

    Ridlerstraße 55

    D-80339 München

    Simon, Franz (DE)

    König & Bauer AG

    Planeta-Bogenoffsetmaschinen

    Postfach 02 01 64

    D-01439 Radebeul

    Veronese, Pancrazio (IT)

    Procter & Gamble

    European Service GmbH

    Sulzbacher Straße 40-50

    D-65823 Schwalbach am Taunus

    Weigel, Matthias (DE)

    Manitz, Finsterwald & Partner

    Patent- und Rechtsanwälte

    Robert-Koch-Straße 1

    D-80538 München

    Weisse, Renate (DE)

    Weisse, Dr. Wolgast & Weisse

    Fuggerstraße 26

    D-10777 Berlin

    Willsau, Peter (DE)

    Raintaler Straße 36

    D-81539 München

    Wolter, Thomas (DE)

    Reitstötter, Kinzebach &

    Partner (GbR)

    Sternwartstraße 4

    D-81679 München

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Baronetzky, Klaus (DE)

    Splanemann Reitzner

    Baronetzky Westendorp

    Rumfordstraße 7

    D-80469 München

    Godemeyer, Thomas (DE)

    Patentanwalt Dr. Thomas Godemeyer

    An den Gärten 7

    D-51491 Overath

    Lauerwald, Jörg (DE)

    Herrmann-Trentepohl

    Grosse - Bockhorni & Partner

    Massenbergstraße 19-21

    D-44787 Bochum

    Reitzner, Bruno (DE)

    Splanemann Reitzner

    Baronetzky Westendorp

    Rumfordstraße 7

    D-80469 München

    Schenkel, Klaus (DE)

    BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH

    Patentabteilung

    Abt ZTP

    Hochstraße 17

    D-81669 München

    Splanemann, Rainer (DE)

    Splanemann Reitzner

    Baronetzky Westendorp

    Rumfordstraße 7

    D-80469 München

    Wiechmann, Manfred (DE)

    c/o ZF Lenksysteme GmbH

    Richard-Bullinger-Straße 77

    D-73527 Schwäbisch Gmünd

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Blochberger, Rainer (DE) - R. 102(1)

    Delitzscher Straße 11

    D-04105 Leipzig

    Buse, Karl Georg (DE) - R. 102(1)

    Patentanwälte

    Buse - Mentzel - Ludewig

    Kleiner Werth 34

    D-42275 Wuppertal

     

    Karau, Wolfgang (DE) - R. 102(1)

    Walter-Bruch-Straße 50

    D-67434 Neustadt

    Rzehak, Herbert (DE) - R. 102(1)

    Dipl.-Phys. Herbert Rzehak

    St.-Blasier-Straße 23

    D-79761 Waldshut-Tiengen

    Tröster, Jürgen (DE) - R. 102(1)

    Akener Bogen 10

    D-06124 Halle

    Walther, Siegfried (DE) - R. 102(1)

    Gußmannstraße 15

    D-01217 Dresden

    Zöllner, Gudrun (DE) - R. 102(1)

    Altenzeller Straße 2-015

    D-01069 Dresden

    ES — Spanien / Spain / Espagne

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Barlocci, Anna (ES)

    Ponti & Tribo S.L.

    Consell de Cent, 322

    E-08007 Barcelona

    FR — Frankreich / France

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Bourdeau, Françoise (FR)

    L'ORÉAL

    Département Propriété Industrielle

    6, rue Bertrand Sincholle

    F-92585 Clichy Cédex

    Cortier, Sophie (FR)

    Fort James France

    Service Propriété Industrielle

    23, boulevard Georges Clemenceau

    FR-92402 Courbevoie Cédex

    David, Alain (FR)

    Cabinet Beau de Loménie

    158, rue de l'Université

    F-75340 Paris Cédex 07

    de Lambilly Delorme, Marie Pierre (FR)

    PSA Peugeot Citroen

    Propriètè Industrielle

    DTAT/MPG/BPI - Service Brevets

    18, rue des Fauvelles

    F-92250 La Garenne Colombes

    Diernaz, Christian (FR)

    Michelin & Cie

    Service SGD/LG/PI-LAD (F35)

    F-63040 Clermont-Ferrand Cédex 09

    Hoey, Shona (GB)

    Rhône-Poulenc Agro

    Département Propriété Industrielle

    B.P. 9163

    F-69263 Lyon Cédex 09

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Cerez-Busnel, Béatrice (FR)

    SAGEM SA

    11, rue Watt

    B.P. 410

    F-75626 Paris Cédex 13

    Lemoyne, Didier (FR)

    France Telecom

    CNET/DSTV/VPI

    38-40, rue du Général Leclerc

    F-92794 Issy-les-Moulineaux Cédex 9

    Marsolais, Richard (FR)

    Péchiney

    Service Brevets

    Immeuble "SIS"

    217, cours Lafayette

    F-69451 Lyon Cédex 06

    Mougeot, Jean-Claude (FR)

    Péchiney

    Service Brevets

    Immeuble "SIS"

    217, cors Lafayette

    F-69451 Lyon Cédex 06

    Pigasse, Daniel (FR)

    Péchiney

    Service Brevets

    Immeuble "SIS"

    217, cours Lafayette

    F-69451 Lyon Cédex 06

    Séraphin, Léon (FR)

    Péchiney

    Service Brevets

    Immeuble "SIS"

    217, cours Lafayette

    F-69451 Lyon Cédex 06

    Vanlaer, Marcel (FR)

    Péchiney

    Service Brevets

    Immeuble "SIS"

    217, cours Lafayette

    F-69451 Lyon Cédex 06

    GB — Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Agnew, Andrew (GB)

    Rhône-Poulenc Rorer Ltd

    London Road

    GB-Holmes Chapel, Cheshire CW4 8BE

    Canning, Lewis R. (GB)

    Nycomed Amersham plc

    White Lion Road

    GB-Amersham, Bucks. HP7 9LL

    Faulkner, Thomas John (GB)

    fJ Cleveland

    40-43 Chancery Lane

    GB-London WC2A 1JQ

    Hockley, Siân Catherine (GB)

    Glaxo Wellcome plc

    Glaxo Wellcome House

    Berkeley Avenue

    GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

    Johnson, Ian Michael (GB)

    Nokia IPR Department

    Nokia House

    Summit Avenue

    GB-Farnborough, Hampshire GU14 0NG

    Marsh, David John (GB)

    Marks & Clerk

    Alpha Tower

    Suffolk Street

    Queensway

    GB-Birmingham B1 1TT

    Marshall, Cameron John (GB)

    Carpmaels & Ransford

    43 Bloomsbury Square

    GB-London WC1A 2RA

    Moy, David (GB)

    Frank B. Dehn & Co.

    179 Queen Victoria Street

    GB-London EC4V 4EL

    Nunn, Andrew Dominic (GB)

    A.A. Thornton & Co.

    4 Freeschool Street

    GB-Northampton NN1 1ST

    Rummler, Felix (DE)

    R.G.C. Jenkins & Co

    26 Caxton Street

    GB-London SW1H 0RJ

    Samuels, Adrian James (GB)

    Frank B. Dehn & Co.

    179 Queen Victoria Street

    GB-London EC4V 4EL

    Shaw, Matthew Nigel (GB)

    Forrester Ketley & Co.

    Chamberlain House

    Paradise Place

    GB-Birmingham B3 3HP

    Strachan, Victoria Jane (GB)

    Marks & Clerk

    24 Athol Street

    GB-Douglas, Isle of Man

    Waddington, Richard (GB)

    Appleyard Lees

    15 Clare Road

    GB-Halifax, West Yorkshire HX1 2HY

    Williams, Ceili (GB)

    Intellectual Property Department

    DERA Farnborough

    Ively Road

    Room G016, A4 Building

    GB-Farnborough, Hants. GU14 0LX

    Williams, Michael Ian (GB)

    Mathys & Squire

    100 Gray's Inn Road

    GB-London WC1X 8AL

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Hector, Annabel Mary (GB)

    Ablett & Stebbing

    Caparo House

    101-103 Baker Street

    GB-London W1M 1FD

    Litchfield, Laura Marie (GB)

    Motorola Limited

    European IP Section

    Law Department

    Midpoint - Alencon Link

    GB-Basingstoke, Hampshire RG21 7PL

    Parker, Nigel Edward (GB)

    67 Delves Crescent

    GB-Walsall, West Midlands WS5 4LS

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Hoey, Shona (GB)

    BP International Limited

    Patents & Agreements

    Research & Engineering

    Chertsey Road

    GB-Sunbury on Tahmes TW16 7LN

    Jenkins, Richard Gray (GB) - R. 102(1)

    R.G.C. Jenkins & Co.

    26 Caxton Street

    GB-London SW1H 0RJ

    IT — Italien / Italy / Italie

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Giberti, Stefano (IT)

    Montell Italia S.p.A.

    Intellectual Property

    Patents & Trademarks

    P.le G. Donegani 12

    I-44100 Ferrara

    Änderungen / Amendments / Modifications

    De Nova, Roberto (IT)

    Viale Cesare Battisti 4

    I-27100 Pavia

    Ghioni, Carlo Raoul Maria (IT)

    Bugnion S.p.A.

    Viale Lancetti 17

    I-20158 Milano

    Macchetta, Francesco (IT)

    Gruppo Lepetit S.p.A.

    Patent Department

    Piazza Türr 5

    I-20149 Milano

    Righetti, Giuseppe (IT)

    Bugnion S.p.A.

    Viale Lancetti 17

    I-20158 Milano

    Sutto, Luca (IT)

    Bugnion S.p.A.

    Viale Lancetti 17

    I-20158 Milano

    Tansini, Elio Fabrizio (IT)

    Bugnion S.p.A.

    Viale Lancetti 17

    I-20158 Milano

    Zanoli, Enrico (IT)

    Montell Italia S.p.A.

    Intellectual Property

    Patents & Trademarks

    P.le G. Donegani 12

    I-44100 Ferrara

    NL — Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Brants, Johan P.E. (BE)

    Arnold & Siedsma

    Sweelinckplein 1

    NL-2517 GK The Hague

    Brouwer, Hendrik Rogier (NL)

    DSM N.V.

    DSM Research B.V.

    BC-NAC

    P.O. Box 18

    NL-6160 MD Geleen

    Verhage, Marinus (NL)

    Octrooibureau Zoan B.V.

    P.O. Box 140

    NL-1380 AC Weesp

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Oelering, Jan Hendrik Johan (NL) - R. 102(1)

    Hofwijkstraat 4

    NL-6825 AL Arnhem

    SE — Schweden / Sweden / Suède

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Aspeby, Magnus (SE)

    Hynell Patenttjänst AB

    Patron Carls väg 2

    S-683 40 Hagfors/Uddeholm

    Axelsson, Nils Ake A.L. (SE)

    Alfa Laval Agri AB

    Patent Department

    S-147 80 Tumba

    Hasselgren, Erik Joakim (SE)

    Alfa Laval AB

    Patents & Trademarks

    P.O. Box 39

    S-147 21 Tumba

    Persson, Eva Kerstin Ch. (SE)

    AB Tetra Pak

    Patent Department

    Ruben Rausings Gata

    S-221 86 Lunt

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Ekström, Nils (SE)

    Göteborgs Patentbyrå Dahls AB

    Sjöporten 4

    S-417 64 Göteborg

    Olsson, Stefan (SE)

    Albihns Patentbyrå Göteborg AB

    P.O. Box 142

    S-401 22 Göteborg

     

    1 Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (epi).

    Adresse :

    Secrétariat epi

    Im Tal 29

    D-80331 Munich

    Tél.: (+49-89)2017080

    FAX: (+49-89)2021548

    e-mail: [email protected]

    Soutien

    • Mises à jour du site Internet
    • Disponibilité de services en ligne
    • FAQ
    • Publications
    • Notifications relatives aux procédures
    • Contact
    • Centre d'abonnement
    • Jours fériés
    • Glossaire

    Centre de presse

    Emploi et carrière

    Single Access Portal

    Achats

    Chambres de recours

    Facebook
    European Patent Office | EPO Jobs
    Instagram
    EuropeanPatentOffice
    Linkedin
    European Patent Office | EPO Jobs | EPO Procurement
    X (formerly Twitter)
    EPOorg | EPOjobs
    Youtube
    TheEPO
    Adresse bibliographiqueConditions d’utilisationProtection des donnéesAccessibilité