European Patent Office
2022

11 - November

Übersicht

Inhaltsverzeichnis
1 - Januar
2 - Februar
3 - März
4 - April
5 - Mai
6 - Juni
7 - Juli
8 - August
9 - September
10 - Oktober
11 - November
12 - Dezember
Zusatzpublikationen
Zusatzpublikationen 1
Zusatzpublikationen 2
Zusatzpublikationen 3

    Artikel 108

    Referenz: ABl. EPA 2022, A108

    Online-Veröffentlichungsdatum: 30.11.2022

    EUROPÄISCHES PATENTAMT
    Vertretung

    Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter1

    Vertragsstaat

    AT

    Österreich

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Clark, Claudia (AT)

    Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

    Dr.-Boehringer-Gasse 5-11

    Schandl, Claudia (AT)

    cf. Clark, Claudia (AT)

    Fox, Tobias (DE)

    Wildhack & Jellinek

    Patentanwälte OG

    Landstraßer Hauptstraße 50

    1030 WIEN

     

    Höferl-Prantz, Kathrin (AT)

    Dr. Weißgatterer Straße 48

    6130 SCHWAZ

    Hotter, Andreas (AT)

    Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

    Dr.-Boehringer-Gasse 5-11

    1121 WIEN

    Mikota, Josef (AT)

    Dynatrace Austria GmbH

    Am Fünfundzwanziger Turm 20

    4020 LINZ

     

    Pucher, Hannes (AT)

    Pucher Patentanwalt

    Merangasse 2

    8010 GRAZ

     

     

     

    BE

    Belgien

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Yang, Puchu (CN)

    Arnold & Siedsma

    Meir 24

    2000 ANTWERPEN

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Preat, Julien (BE)

    Umicore

    Rue du Marais 31

    1000 BRUSSELS

    Vanoppen, Ronny R.J. (BE)

    Bureau M.F.J. Bockstael N.V.

    Arenbergstraat 13

    2000 ANTWERPEN

     

     

    CH

    Schweiz

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Böckmann genannt Dallmeyer, Georg Nikolas (DE)

    cf. LI

    Keller & Partner Patentanwälte AG

    Patent- und Markenanwälte AG

    Eigerstrasse 2

    Postfach

    3000 BERN 14

    Enmon, Jennifer Lynn (US)

    Société des Produits Nestlé S.A.

    Avenue Nestlé 55

    1800 VEVEY

    Mizbani, Amir (IR)

    F. Hoffmann-La Roche Ltd

    Grenzacherstrasse 124

    4070 BASEL

     

    Zaichuk, Mariana (UA)

    Neurimmune AG

    Wagistrasse 18

    8953 SCHLIEREN

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Dubes, Alix (FR)

    Bristol-Myers Squibb

    Intellectual Property

    Hinterbergstrasse 16

    6312 STEINHAUSEN

    Gundel, Isabelle (DE)

    GSK Consumer Healthcare SARL

    (Haleon Group)

    Route de l'Etraz

    1260 NYON

    Kling, Edouard (FR)

    Bristol-Myers Squibb

    Intellectual Property

    Hinterbergstrasse 16

    6312 STEINHAUSEN

     

    Rauh, Sabine (DE)

    Burgunderweg 23

    4106 THERWIL

    Zwick, Evelyn (CH)

    EZ-Patent GmbH

    Stuhlenstrasse 13

    8123 EBMATINGEN

     

     

    DE

    Deutschland

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Canbolat Tugrul, Eylem (TR)

    Wella Germany GmbH

    Berliner Allee 65

    64295 DARMSTADT

    Gangl, Cordula (DE)

    Winter, Brandl Partnerschaft mbB

    Patentanwälte

    Bavariaring 10

    80336 MÜNCHEN

    Gao, Lin (CN)

    IP2 Patentanwalts GmbH

    Schlossstraße 523-525

    41238 MÖNCHENGLADBACH

     

    Kienitz, Jens Sebastian (DE)

    HGF Europe LLP

    Neumarkter Straße 18

    81673 MÜNCHEN

    Kim, Dongman (KR)

    Hoffmann Eitle

    Patent- und Rechtsanwälte PartmbB

    Arabellastraße 30

    81925 MÜNCHEN

    Kitaura, Saeri (JP)

    Grünecker

    Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB

    Leopoldstraße 4

    80802 MÜNCHEN

     

    Lajtkep, Angela Sandra (DE)

    Epping Hermann Fischer

    Patentanwalts­gesellschaft mbH

    Schloßschmidstraße 5

    80639 MÜNCHEN

    Schäfer, Gerd (DE)

    BASF SE

    Carl-Bosch-Straße 38

    67056 LUDWIGSHAFEN

    Sun, Yanan (CN)

    Hassler International Germany GmbH

    Textorstraße 91

    60596 FRANKFURT AM MAIN

     

    Tu, Yu-Kuan (TW)

    Wuesthoff & Wuesthoff

    Patentanwälte PartG mbB

    Schweigerstraße 2

    81541 MÜNCHEN

    Uchiyama, Yuko (JP)

    Global IP Europe

    Patentanwalts­kanzlei

    Pfarrstraße 14

    80538 MÜNCHEN

    Westphal, Dieter (DE)

    Untere Dorfstraße 26

    85402 KRANZBERG

     

    Yamazaki, Takahiro (JP)

    Meissner Bolte

    Patentanwälte Rechtsanwälte

    Partnerschaft mbB

    Widenmayerstraße 47

    80538 MÜNCHEN

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Aspacher, Karl-Georg (DE)

    Entenbachstraße 12 Rgb

    81541 MÜNCHEN

    Beier, Ralph (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Bellingacci, Riccardo (IT)

    ZSP

    Patentanwälte PartG mbB

    Hansastraße 32

    80686 MÜNCHEN

     

    Blackledge, Charles Wesley (US)

    Lauterstraße 8

    12159 BERLIN

    Bobbert, Christiana (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Nordostpark 30

    90411 NÜRNBERG

    Bode, Birte (DE)

    Bode Patentanwalte PartGmbB

    Ringhofferstraße 12

    85716 UNTERSCHLEIßHEIM

     

    Bonn, Roman Klemens (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Putzbrunnerstraße 69

    81739 MÜNCHEN

    Boss, Marcel (DE)

    Breuerwiesenstraße 55

    65929 FRANKFURT AM MAIN

    Brossart, Anton (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

     

    Bublak, Wolfgang (DE)

    Stolmár & Partner

    Patentanwälte PartG mbB

    Blumenstraße 17

    80331 MÜNCHEN

    Büchner, Jörg (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Nordostpark 30

    90411 NÜRNBERG

    Despalle, Pierre-Aimé (FR)

    ResMed Germany Inc.

    Fraunhoferstraße 16

    82152 MARTINSRIED

     

    Dittmer, Thomas (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Sodener Straße 9

    65824 SCHWALBACH AM TAUNUS

    Echterhoff, Benjamin Alexander (DE)

    Implerstraße 66

    81371 MÜNCHEN

    Erbe, Claudia (DE)

    TE Connectivity Germany GmbH

    Ampèrestraße 12 - 14

    64625 BENSHEIM

     

    Erden, Lejs Mersid (DE)

    Leica Microsystems CMS GmbH

    Am Friedensplatz 3

    68165 MANNHEIM

    Ferstl, Pascal Stefan (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Gebauer, Olaf (DE)

    Bayer Intellectual Property GmbH

    IPO-P, TASMI

    Alfred-Nobel-Straße 50

    40789 MONHEIM

     

    Goedel, Kathrin (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Putzbrunnerstraße 69

    81739 MÜNCHEN

    Grödl, Felix Veit (DE)

    Flach Bauer & Partner

    Patentanwälte mbB

    Adlzreiterstraße 11

    83022 ROSENHEIM

    Grundner, Sebastian (DE)

    Siltronic AG

    Intellectual Property

    Johannes-Hess-Straße 24

    84489 BURGHAUSEN

     

    Hertz, Oliver (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Heusler, Wolfgang (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Hibst, Nicolas (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Nordostpark 30

    90411 NÜRNBERG

     

    Katzameyer, Michael (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Kotitschke, Bernd (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Lee, Jun-Hoe Daniel (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

     

    Löbig, Norbert (DE)

    Am Hohen Weg 20

    82288 KOTTGEISERING

    Maier, Stefan Josef (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Putzbrunnerstraße 69

    81739 MÜNCHEN

    McConnell, Roderick (US)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Putzbrunnerstraße 69

    81739 MÜNCHEN

     

    Michelsen, Markus (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

    Neumann, Stephan (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

    Pavan, Andrea (IT)

    Vossius & Partner

    Patentanwälte Rechtsanwälte mbB

    Siebertstraße 3

    81675 MÜNCHEN

     

    Poganiuch, Peter (DE)

    Winterbergstraße 18

    67434 NEUSTADT/WSTR.

    Pommerin, Christian Andreas Valentin (DE)

    Siemens Mobility GmbH

    Klaus-Bungert-Straße 6

    40468 DÜSSELDORF

    Prunhuber, Tobias Ludwig (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

     

    Reichert, Christian (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Reuter, Andreas (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Nordostpark 30

    90411 NÜRNBERG

    Rinn, Matthias (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

     

    Rosenthal, Oliver (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Rothfelder, Marcel Philipp (DE)

    Infineon Technologies AG

    Am Campeon 1-15

    85579 NEUBIBERG

    Saal, Hilkka (DE)

    Tesa SE

    Hugo-Kirchberg-Straße 1

    22848 NORDERSTEDT

     

    Sattler, Matthias (DE)

    Schott AG

    Hattenbergstraße 10

    55122 MAINZ

    Schmid-Dochnahl, Marie-Theres (DE)

    Pateris

    Patentanwälte PartmbB

    Rosenheimer Straße 143c

    81671 MÜNCHEN

    Schober, Ralf Stefan (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Putzbrunnerstraße 69

    81739 MÜNCHEN

     

    Schramm, Thomas Harald (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

    Seeger, Bastian (DE)

    v. Bezold & Partner

    Patentanwälte - PartG mbB

    Ridlerstraße 57

    80339 MÜNCHEN

    Smit, Marco (NL)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Sodener Straße 9

    65824 SCHWALBACH AM TAUNUS

     

    Thiel, Linda (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

    Thies, Stephan (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Sodener Straße 9

    65824 SCHWALBACH AM TAUNUS

    Tilmann, Max Wilhelm (DE)

    Alt-Niederkassel 62

    40547 DÜSSELDORF

     

    von Westernhagen, Karsten (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Patente & Lizenzen

    Guerickestraße 7

    60488 FRANKFURT AM MAIN

    Wagner, Philipp (DE)

    Continental Automotive Technologies GmbH

    Intellectual Property

    Nordostpark 30

    90411 NÜRNBERG

    Wiesemann, Nikola (DE)

    df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman

    Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB

    Theatinerstraße 16

    80333 MÜNCHEN

     

    Wollschlaeger, Carolin (DE)

    Hoyng Rokh Monegier

    Steinstraße 20

    40212 DÜSSELDORF

     

     

     

    Löschungen

     

     

     

    Köckeritz, Günter (DE)

    R. 154(1)

    Bressel und Partner mbB

    Patentanwälte

    Park Kolonnaden

    Potsdamer Platz 10

    10785 BERLIN

    Seelert, Stefan (DE)

    R. 154(1)

    Basell Polyolefine GmbH

    Intellectual Property

    Bldg. E413, 5.OG

    Industriepark Hoechst

    65926 FRANKFURT AM MAIN

    Tergau, Dietrich (DE)

    R. 154(2)(a)

    Tergau & Walkenhorst

    Patentanwälte PartGmbB

    Längenstraße 14

    90491 NÜRNBERG

     

    Zerbes, Valentin (DE)

    cf. SE

    Webasto SE

    Kraillinger Straße 5

    82131 STOCKDORF

     

     

     

    DK

    Dänemark

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Amery, Marcus James (GB)

    Rockwool A/S

    Group Patents

    Hovedgaden 584C

    2640 HEDEHUSENE

    Bækmark, Thomas Rosleff (DK)

    Nex & Phister Law & IP ApS

    Ole Maaløes Vej 3

    2200 KØBENHAVN N

    Garde, Charlotte Kammer (DK)

    Novo Nordisk Fonden

    Tuborg Havnevej 19

    2900 HELLERUP

     

    Jensen, Kent Winther (DK)

    Chas Hude A/S

    Langebrogade 1, 2., B2

    1411 KØBENHAVN K

    Justesen, Jeannette Hoffmann Frisch (DK)

    Genmab A/S

    Kalvebod Brygge 43

    1560 KØBENHAVN V

    Kjerrumgaard, Lars Bo (DK)

    Nex & Phister Law & IP ApS

    Cobis Ole Maaløes Vej 3

    2200 KØBENHAVN N

     

    EE

    Estland

     

     

     

    Löschungen

     

     

     

    Urgas, Enn (EE)

    R. 154(1)

    Patendibüroo Turvaja OÜ

    Liivalaia 22

    10118 TALLINN

     

     

     

    ES

    Spanien

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    De la Colina Montero, Maria Rosa (ES)

    Isern Patentes y Marcas, S.L.

    C/Principe de Vegara 43, 6 planta

    28001 MADRID

    González Fuentes, María (ES)

    Neuraxpharm

    Avenida de Barcelona, 69

    08970 SANT JOAN DESPI, BARCELONA

    Mariné, Diana (ES)

    ABG Intellectual Property Law, S.L.

    Avenida de Burgos, 16 D

    Edificio Euromor

    28036 MADRID

     

    Löschungen

     

     

     

    Gómez Gil, Leticia (ES)

    cf. NL

    Pons Consultores de la Propriedad Industrial, S.A

    Glorieta Rubén Darío 4

    28010 MADRID

    Morales Duran, Carmen (ES)

    R. 154(2)(a)

    Clarke, Modet & Co.

    Suero de Quiñones, 34-36

    28002 MADRID

     

     

    FI

    Finnland

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Aromaa, Sami Rainer (FI)

    Polar Electro Oy

    Professorintie 5

    90440 KEMPELE

     

     

     

    FR

    Frankreich

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Buratto, Sébastien Jean (FR)

    TotalEnergies OneTech

    CSTJF - Avenue Larribau

    64018 PAU CEDEX

    Houppe, Marie (FR)

    Novagraaf Technologies SA

    2, rue Sarah Bernhardt

    CS 90017

    92665 ASNIÈRES-SUR-SEINE CEDEX

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Alami, Hamza (FR)

    IPAZ

    16, rue Gaillon

    75002 PARIS

    Bernos, Julien (FR)

    Pasqal SAS

    7, rue Léonard de Vinci

    91300 MASSY

    Grout de Beaufort, François-Xavier (FR)

    Institut national de la propriété industrielle

    15, rue des Minimes

    92677 COURBEVOIE CEDEX

     

    Loubet, Bruno Thomas (FR)

    Plasseraud IP

    66, rue de la Chaussée d'Antin

    75440 PARIS CEDEX 09

    Pignier, Alexandre John André (FR)

    Withings

    2, rue Maurice Hartmann

    92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

    Plagnard, Thomas Eric (FR)

    Withings

    2, rue Maurice Hartmann

    92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

     

    Löschungen

     

     

     

    Kickler, Nils (DE)

    R. 154(1)

    Brevalex

    22, avenue Doyen Louis Weil

    38024 GRENOBLE CEDEX 1

     

     

     

    GB

    Vereinigtes Königreich

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Bagnall, Georgina Nancy (GB)

    Franks & Co Limited

    15 Jessops Riverside

    Brightside Lane

    SHEFFIELD S9 2RX

    Hardisty, Robyn Elizabeth (GB)

    Haseltine Lake Kempner LLP

    Redcliff Quay

    120 Redcliff Street

    BRISTOL BS1 6HU

    Li, Ningning (CN)

    Hindles Limited

    Clarence House

    131-135 George Street

    EDINBURGH EH2 4JS

     

    Mather, Christian Alexander (GB)

    Dehns

    The Brinell Building

    30 Station Street

    BRIGHTON BN1 4RB

    McGuinness, Conor Joseph (GB)

    Finnegan Europe LLP

    1 London Bridge

    LONDON SE1 9BG

    Melhirst, Daniel Neal (GB)

    Refeyn Ltd

    1 Electric Avenue

    Ferry Hinksey Road

    OXFORD OX2 0BY

     

    Rajagopal, Sudarsan (IN)

    Carpmaels & Ransford LLP

    One Southampton Row

    LONDON WC1B 5HA

    Tough, Daniel (GB)

    Withers & Rogers LLP

    Bank 26

    28 High Street

    WARWICK CV34 4BE

    Walsh, Matthew James (GB)

    Potter Clarkson LLP

    The Belgrave Centre

    Talbot Street

    NOTTINGHAM NG1 5GG

     

    White, Alexander Thomas (GB)

    Ecclesall IP Ltd.

    44 Ranby Road

    SHEFFIELD S11 7AJ

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Auger, James Michael (GB)

    British Telecommunications plc

    Intellectual Property Department

    9th Floor

    1 Braham Street

    LONDON E1 8EE

    Aylett, Sophie-Beth (GB)

    HGF Limited London

    Central Court

    25 Southampton Buildings

    LONDON WC2A 1AL

    Baker, Louise Nicola (GB)

    HGF Limited

    Cavendish House

    39-41 Waterloo Street

    BIRMINGHAM B2 5PP

     

    Bannister, Matthew David (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Clacy, Dominic Ian (GB)

    Openshaw & Co.

    8 Castle Street

    FARNHAM, SURREY GU9 7HR

    Codd, Matthew David (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Collerton, Catriona Louise (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Daniels, Jeffrey Nicholas (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Deb, Roona (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Driver, Virginia Rozanne (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Evans, Marc Nigel (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Flint, Adam (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Gill, Sharaz Michael (GB)

    Invenza Ltd

    301 Searles Court

    4 Rolfe Terrace

    LONDON SE18 6BS

    Gill-Carey, Michael (GB)

    Haleon

    5 The Heights

    Wellington Way

    WEYBRIDGE, SURREY KT13 0NY

    Jenkins, Peter David (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Jinks, Samuel (GB)

    Haley Guiliano International LLP

    26-28 Bedford Row

    LONDON WC1R 4HE

    Judge, Samuel David (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Keeling, Thomas Michael (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Kent, Miranda Jacket (GB)

    Dyson Technology Limited

    Tetbury Hill

    MALMESBURY, WILTSHIRE SN16 0RP

    Lee, Alexander Mark (GB)

    HGF

    Biocity

    Pennyfoot Street

    NOTTINGHAM NG1 1GF

    Lobban, Colin (GB)

    Dyson Technology Limited

    Tetbury Hill

    MALMESBURY, WILTSHIRE SN16 0RP

     

    Lubienski, Michael John (GB)

    Haleon

    5 The Heights

    Wellington Way

    WEYBRIDGE, SURREY KT13 0NY

    Mahon, Thomas James (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Martinez, Olivier Gildas (FR)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Martynwood, Gemma Holly (GB)

    EIP Europe LLP

    Fairfax House

    15 Fulwood Place

    LONDON WC1V 6HU

    McKinlay, Andrew James (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Mills, Elizabeth Rose (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Morris, Jonathan Paul (GB)

    Murgitroyd & Company

    Studio H1B

    297 Upper Fourth Street

    Witan Studios

    MILTON KEYNES MK9 1EH

    Mukhtar, Amira (GB)

    Walgreens Boots Alliance

    1 Thane Road West

    NOTTINGHAM NG90 1BS

    Munro, Katherine Elizabeth (GB)

    EIP

    Suite 4, Level 6

    Broad Gate

    22-26 The Headrow

    LEEDS LS1 8EQ

     

    O'Kane, Sean Martin (IE)

    Ocado Group IP Department

    Buildings 1 and 2 Trident Place

    Hatfield Business Park

    Mosquito Way

    HATFIELD AL10 9UL

    Peel, Katherine Jane (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Roberts, David (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Rollinson, Gabrielle Mary Joy (GB)

    Crown Packaging Manufacturing Ltd

    c/o Downsview Road

    WANTAGE, OXFORDSHIRE OX12 9BP

    Ruuskanen, Juha-Pekka (FI)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Slope, Louise Nicola (GB)

    cf. Baker, Louise Nicola (GB)

     

    Smith, Gary John (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Stephens, Clare Jean (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Style, Kelda Camilla Karen (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Sweetinburgh, Mark Roger (GB)

    Sweetinburgh & Windsor

    Churchill Court

    3 Manor Royal

    CRAWLEY, WEST SUSSEX RH10 9LU

    Thompson, Andrew John (GB)

    EIP Europe LLP

    Fairfax House

    15 Fulwood Place

    LONDON WC1V 6HU

    Townsend, Martyn (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    van den Bent-Kelly, Andrew Paul (GB)

    Mathys & Squire LLP

    The Shard

    32 London Bridge Street

    LONDON SE1 9SG

    Weston, Dominic James (GB)

    Page White & Farrer Services

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

    Williams, David John (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

    Windsor, Louise (GB)

    Sweetinburgh & Windsor

    Churchill Court

    3 Manor Royal

    CRAWLEY, WEST SUSSEX

    RH10 9LU

    Winlow, Eden Thomas (GB)

    Bristows LLP

    100, Victoria Embankment

    LONDON EC4Y 0DH

    Wooden, Gemma Holly (GB)

    cf. Martynwood, Gemma Holly (GB)

     

    Woodhouse, Thomas Duncan (GB)

    Page, White & Farrer Limited

    Bedford House

    21A John Street

    LONDON WC1N 2BF

     

     

     

    IE

    Irland

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Bo, Lin (CN)

    Murgitroyd & Company

    2nd Floor

    57 Adelaide Road, Saint Kevin's

    DUBLIN 2, D02 Y3C6

     

     

     

    IT

    Italien

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Bartorelli, Luisa (IT)

    Studio Legale Bird & Bird

    Via Porlezza, 12

    20123 MILANO

    Bettello, Pietro (IT)

    Studio Tecnico

    Ing. Pietro Bettello

    Via Col d'Echele 25

    36100 VICENZA

    Calogero, Ida (IT)

    Studio Legale Bird & Bird

    Via Porlezza, 12

    20123 MILANO

     

    De Gregori, Antonella (IT)

    Studio Legale Bird & Bird

    Via Porlezza, 12

    20123 MILANO

    De Ros, Alberto (IT)

    Studio Legale Bird & Bird

    Via Porlezza, 12

    20123 MILANO

    Fattori, Michele (IT)

    Via Umberto Zurlini, 130

    41125 MODENA

     

    Salerno, Antonio (IT)

    Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l.

    Via Larga, 16

    20122 MILANO

    Sulcis, Roberta (IT)

    Fresenius Kabi iPSUM s.r.l.

    Via San Leonardo, 23

    45010 VILLADOSE

     

     

    LI

    Liechtenstein

     

     

     

    Löschungen

     

     

     

    Böckmann genannt Dallmeyer,

    Georg Nikolaus (DE)

    cf. CH

    Kaminski Harmann

    Patentanwälte AG

    Landstrasse 124

    9490 VADUZ

     

     

     

    LU

    Luxemburg

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Machtalère, Georges (FR)

    16, rue du Maréchal Foch

    1527 LUXEMBOURG

     

     

     

    NL

    Niederlande

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Debbarma, Diptanil (IN)

    NLO

    New Babylon City Offices

    Anna van Buerenplein 21a

    2595 DA DEN HAAG

    Gómez Gil, Leticia (ES)

    cf. ES

    UniQure N.V.

    Paasheuvelweg 25

    1105 BP AMSTERDAM

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Kamphuis, Alex (NL)

    Arnold & Siedsma

    Bezuidenhoutseweg 57

    2594 AC DEN HAAG

    Lähteenmäki, Laura Johanna (FI)

    Kverneland Group Europe B.V.

    Hoofdweg 1278

    2153 LR NIEUW-VENNEP

     

     

    SE

    Schweden

     

     

     

    Eintragungen

     

     

     

    Enetoft, Daniel (SE)

    Liljevägen 1

    232 54 ÅKARP

    Zerbes, Valentin (DE)

    cf. DE

    Essity Hygiene and Health AB

    Essity IP Department

    405 03 GÖTEBORG

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Cao, Cao (SE)

    Groth & Co KB

    Box 6107

    102 32 STOCKHOLM

    Rystedt, Per Hampus (SE)

    Olink Proteomics AB

    Dag Hammarskjölds väg 52B

    752 37 UPPSALA

     

     

    TR

    Türkei

     

     

     

    Änderungen

     

     

     

    Mert, Ebru (TR)

    Seyh Samil mah. Eylul sok.

    Yenikent kardelen sitesi No: 1/48

    42110 SELCUKLU/‌KONYA

     

     

     

     

    1 Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (epi).
    Anschrift:
    epi-Sekretariat
    Bayerstr. 83
    80335 München
    Deutschland
    Tel. +49 (0)89 242052-0
    Fax +49 (0)89 242052-220
    [email protected]

    Unterstützung

    • Aktualisierungen der Website
    • Verfügbarkeit der Online-Dienste
    • FAQ
    • Veröffentlichungen
    • Verfahrensbezogene Mitteilungen
    • Kontakt
    • Aboverwaltung
    • Offizielle Feiertage
    • Glossar

    Jobs & Karriere

    Pressezentrum

    Single Access Portal

    Beschaffung

    Beschwerdekammern

    Facebook
    European Patent Office | EPO Jobs
    Instagram
    EuropeanPatentOffice
    Linkedin
    European Patent Office | EPO Jobs | EPO Procurement
    X (formerly Twitter)
    EPOorg | EPOjobs
    Youtube
    TheEPO
    ImpressumNutzungsbedingungenDatenschutzBarrierefreiheit