European Patent Office
1994

6 - juin

Vue d'ensemble

Table des matières
1-2 - janvier - février
3 - mars
4 - avril
5 - mai
6 - juin
7 - juillet
8 - août
9 - septembre
10 - octobre
11 - novembre
12 - décembre
Suppléments / Éditions spéciales
Supplément to OJ 4/1994
Supplément to OJ 6/1994
Supplément to OJ 9/1994
Éditions spéciales

    Pages 433-436

    Référence : JO OEB 1994, 433

    Date de publication en ligne: 30.6.1994

    REPRÉSENTATION

    Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets*

    BE — Belgien / Belgium / Belgique

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Pirson, Jean (BE)

    Avenue Van Crombrugghe, 188

    B-1050 Bruxelles

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Bossard, Franz (CH) - R. 102(1)

    288, rue de Jamioulx

    B-6110 Montigny-le-Tilleul

    CH — Schweiz / Switzerland / Suisse

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Weiss, Wolfgang (DE)

    Bühler AG

    Patentabteilung

    CH-9240 Uzwil

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Utiger, Heinrich (CH)

    Postfach 77

    David-Hess-Weg 16

    CH-8060 Zürich

    DE — Deutschland / Germany / Allemagne

    Eintragungen / Entries / Inscriptions

    Janotte, Michael (DE)

    Säbenerstraße 38

    D-81547 München

    Schwarz, Ralf (DE)

    Boehringer Mannheim GmbH

    Patentabteilung

    Sandhofer Straße 116

    D-68298 Mannheim

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Endlich, Fritz (DE)

    Lieck, Endlich & Partner

    Postfach 13 26

    D-82101 Germering

    Esser, Wolfgang (DE)

    Deutsche ITT Industries GmbH

    ITT Regional Patent Office - Europe

    Hans-Bunte-Straße 19

    D-79108 Freiburg

    Lieck, Hans-Peter (DE)

    Lieck, Endlich & Partner

    Widenmayerstraße 36

    D-80538 München

    Lisowski, Horst (DE)

    Carl-Justi-Straße 34

    D-53121 Bonn

    Parske, Matthias (DE)

    Erich-Weinert-Straße 75

    D-10439 Berlin

    Raß, Johann (DE)

    Siemens AG

    GR PA 7

    Postfach 22 16 34

    D-80506 München

    Riedel, Peter (DE)

    c/o Patentanwalt

    Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner

    Menzelstraße 40

    D-70192449 Stuttgart

    Rupprecht, Kay (DE)

    Lieck, Endlich & Partner

    Widenmayerstraße 36

    D-80538 München

    Tesch, Rudolf (DE)

    Postfach 428

    D-79230 March

    Wappler, Christine (DE)

    Heidestraße 20

    D-01474 Weißig

    Weißfloh, Ingo (DE)

    Prellerstraße 26

    D-01309 Dresden

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Heinecke, Horst (DE) - R. 102(1)

    Kastanienweg 60

    D-08060 Zwickau

    Hesse, Volker (DE) - R. 102(1)

    Saturnstraße 65

    D-04205 Leipzig

    Köthe, Günter (DE) - R. 102(1)

    Güntherstraße 12

    D-10318 Berlin

    Ochmann, Eckhard (DE) - R. 102(1)

    Deutsche Reichsbahn

    Hauptprüfungsamt

    Ruscherstraße 59

    D-10322 Berlin

    Rothenburger, Michael (DE) - R. 102(1)

    Novalisstraße 15

    D-07747 Jena

    Weiss, Wolfgang (DE) - cf. CH

    Karl-Marx-Straße 68

    D-68199 Mannheim

    FR — Frankreich / France

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Chaillot, Geneviève (FR)

    Cabinet Chaillot

    Le Ravel - Hall A

    16-20, Avenue de l'Agent Sarre

    F-92700 Colombes

    Colombet, Alain André (FR)

    Cabinet Bernasconi et Vigier

    2, rue de la Claire

    F-69257 Lyon Cédex 09

    Loraux, Jean-Claude Georges (FR)

    47, Boulevard de l'Hôpital

    Ecole des Infirmières

    F-75013 Paris

    Rataboul, Michel Charles (FR)

    CMR International

    10, rue de Florence

    F-75008 Paris

    Tilliet, René Raymond Claude (FR)

    4, Avenue Pasteur

    F-78340 Les Clayes Sous Bois

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Gori, Guy (FR) - R. 102(1)

    ONERA

    BP 72

    F-92320 Châtillon

    Kohn, Armand (FR) - R. 102(1)

    5, avenue Foch

    F-92380 Garches

    GB — Vereinigtes Königreich/ United Kingdom / Royaume-Uni

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Andrews, Arthur Stanley (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    Blum, Robert Alan (GB)

    Gill Jennings & Every

    Broadgate House

    7 Eldon Strett

    GB-London EC2M 7LH

    Boxall, Robin John (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    Clark, Jane Anne (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    Colmer, Stephen Gary (GB)

    Mobil Services Company Limited

    Patent Department

    Mobil House

    50-60 Victoria Street

    GB-London SW1E 6QB

    Curtis, Philip Anthony (GB)

    Mobil Services Company Limited

    Patent Department

    Mobil House

    50-60 Victoria Street

    GB-London SW1E 6QB

    Eyles, Christopher Thomas (GB)

    W.P. Thompson & Co.

    Celcon House

    289-293 High Holborn

    GB-London WC1V 7HU

    Frain, Timothy John (GB)

    Nokia Mobile Phones

    St. Georges Court

    St. Georges Road

    GB-Camberley, Surrey GU15 3QZ

    Freeman, Jacqueline Carol (GB)

    W.P. Thompson & Co.

    Celcon House

    289-293 High Holborn

    GB-London WC1V 7HU

    Greaves, Carol Pauline (GB)

    Mewburn Ellis

    St. Lawrence House

    Broad Street

    GB-Bristol BS1 2HU

    Hector, Annabel Mary (GB)

    W.P. Thompson & Co.

    Celcon House

    289-293 High Holborn

    GB-London WC1V 7HU

    Jones, Ian (GB)

    W.P. Thompson & Co.

    Celcon House

    289-293 High Holborn

    GB-London WC1V 7HU

    Kidd, Piers Burgess (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    Moody, Colin James (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    Oliver, Roy Edward (GB)

    W.P. Thompson & Co.

    Celcon House

    289-293 High Holborn

    GB-London WC1V 7HU

    Roberts, Peter William (GB)

    Mobil Services Company Limited

    Patent Department

    Mobil House

    50-60 Victoria House

    GB-London SW1E 6QB

    Stevens, Brian Thomas (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    White, Andrew Gordon (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    Williamson, Paul Lewis (GB)

    Philips Electronics UK Limited

    Patents and Trade Marks Department

    Cross Oak Lane

    GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Robertson, Michael Mundie (GB) - R. 102(1)

    ICI Group Patents Services Dept.

    PO Box 6

    Shire Park

    Bessemer Road

    GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD

    Smith, Geoffrey Leonard (GB) - R. 102(1)

    Sheppies

    6 The Green

    GB-Chipping Campden, Glos. GL55 6DL

    IT — Italien / Italy / Italie

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Faraggiana, Vittorio (IT)

    Ingg. Guzzi & Ravizza S.r.l.

    Via Vincenzo Monti 8

    I-20123 Milano

    NL — Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

    Löschungen / Deletions / Radiations

    Grotepas, Frans (NL) - R. 102(1)

    Lijsterlaan 11

    NL-5561 TJ Riethoven

    PT — Portugal

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Carvalho Franco, Isabel (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195-r/c-D

    P-1200 Lisboa

    Dinis de Carvalho, José Eduardo (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195-r/c-D

    P-1200 Lisboa

    Moreira Rato, Gonçalo (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195-r/c-D

    P-1200 Lisboa

    Olavo, Carlos Fernando (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195-r/c-D

    P-1200 Lisboa

    Ramos Pimenta, Joao Manuel (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195-r/c-D

    P-1200 Lisboa

    Sampaio, Antonio Luis de (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195-r/c-D

    P-1200 Lisboa

    Sampaio, José Eduardo de (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195 r/c-D

    P-1200 Lisboa

    van Zeller Garin, Jorge (PT)

    J.E. Dias Costa Lda.

    Rua do Salitre, 195-r/c-D

    P-1200 Lisboa

    SE — Schweden / Sweden / Suède

    Änderungen / Amendments / Modifications

    Dahlstrand, Björn (SE)

    Asea Brown Boveri AB

    Patent

    Stockholm Office

    S-120 86 Stockholm

    Holmborn, Erland Karl (SE)

    Scania CV AB

    Patents, BLY

    S-151 87 Södertälje

    Jenkler, Malte (SE)

    Asea Brown Boveri AB

    Patent

    Stockholm Office

    S-120 86 Stockholm

    _______

    * Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut

    EPI-Secrétariat général

    Erhardtstrasse 27,

    D-80331 Munich

    Tél. (+49-89)2017080,

    Tx. 5/216834,

    FAX (+49-89)2021548.

    Soutien

    • Mises à jour du site Internet
    • Disponibilité de services en ligne
    • FAQ
    • Publications
    • Notifications relatives aux procédures
    • Contact
    • Centre d'abonnement
    • Jours fériés
    • Glossaire

    Centre de presse

    Emploi et carrière

    Single Access Portal

    Achats

    Chambres de recours

    Facebook
    European Patent Office | EPO Jobs
    Instagram
    EuropeanPatentOffice
    Linkedin
    European Patent Office | EPO Jobs | EPO Procurement
    X (formerly Twitter)
    EPOorg | EPOjobs
    Youtube
    TheEPO
    Adresse bibliographiqueConditions d’utilisationProtection des donnéesAccessibilité